3116808 CANADA INC. (Corporation# 3116808) is a federal corporation entity registered with Corporations Canada. The incorporation date is February 9, 1995.
Corporation ID | 3116808 |
Corporation Name | 3116808 CANADA INC. |
Incorporation Date | 1995-02-09 |
Corporation Status | Active / Actif |
Address |
1000, Rue De La Gauchetière Ouest 2500 Montréal QC H3B 0A2 Canada |
Business Number | 140758640 |
Governing Legislation |
Canada Business Corporations Act (CBCA) Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) |
Number of Directors | 1 - 10 |
Director Name | Director Address |
---|---|
LOUIS AUBUCHON | 4837, COLLÈGE-BEAUBOIS, MONTRÉAL QC H8Y 3T2, Canada |
Thierry Brossard | 21, Beauchamp, Mercier QC J6R 2K2, Canada |
Patrick Malo | 8420, rue Charles-Huot, Mirabel QC J7N 3J7, Canada |
Heather McCrory | 3205 - 1 Market Street, Toronto ON M5E 0A2, Canada |
Date | Previous Name |
---|---|
1995-02-09 - 2019-12-15 | 3116808 CANADA INC. |
Date | Activity |
---|---|
1995-02-09 | Incorporation / Constitution en société |
Year | Annual Meeting | Corporation Type |
---|---|---|
2019 | 2018-04-23 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2018 | 2017-05-02 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
2017 | 2016-04-21 | Non-distributing corporation with 50 or fewer shareholders Société n'ayant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins |
Address | 1000, rue De La Gauchetière Ouest |
City | Montréal |
Province | QC |
Postal Code | H3B 0A2 |
Country | Canada |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
Eksmo Agency Inc. | 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, MontrÉal, QC H3B 4W5 | 1998-11-23 |
Les Entreprises Tony Beaulieu Inc. | 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 | 1980-01-25 |
France Telecom Canada Inc. | 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 0A2 | 1998-12-24 |
Oria Capital Inc. | 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Montreal, QC H3B 5H4 | 2000-01-01 |
Corporation De Gestion Wbi · Wbi Holding Corporation | 1000, Rue De La GauchetiÈre Ouest, Montreal, QC H3B 4W5 | 2004-01-19 |
4373359 Canada Inc. | 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 | 2006-10-05 |
4373367 Canada Inc. | 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 | 2006-10-05 |
159349 Canada Inc. | 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 | |
Canada Corner Inc. | 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 | 2006-05-15 |
Clinirecherche Inc. | 1000, Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, QC H3B 4W5 | 1982-09-29 |
Find all corporations in the same location |
Corporation Name | Office Address | Incorporation |
---|---|---|
9332073 Canada Inc. | 2500-1000 De La Gauchetière Street West, Montréal, QC H3B 0A2 | 2017-12-22 |
8504741 Canada Inc. | 2500-1000 De La Gauchetière West, Montreal, QC H3B 0A2 | 2014-08-28 |
Plaza Des Seigneurs Holdings Inc. · Placements Plaza Des Seigneurs Inc. | 100 De La Gauchètiere West, Montréal, QC H3B 0A2 | 2011-12-22 |
Place Desormeaux Holdings Inc. · Placements Place Desormeaux Inc. | 1000 De La Gauchetière West, Suite 2500, Montreal, QC H3B 0A2 | 2011-08-22 |
Monaxxion Enterprises Corporation | 1000, De La Gauchetière Ouest, 24e étage, Montréal, QC H3B 0A2 | 2010-07-06 |
Planet Finance Canada | 2500 - 1000 Rue De La Gauchetière Ouest, Montreal, QC H3B 0A2 | 2007-10-15 |
Savage Canac Corporation · Corporation Savage Canac | Suite 2500, 1000 Rue De La Gauchetiere O, Montreal, QC H3B 0A2 | 2004-04-23 |
Competitor Canada, Inc. | 1000 Rue De La Gauchetière West, Montreal, QC H3B 0A2 | 1985-11-28 |
Canaglobe International Inc. · Conseillers Canaglobe Ltee | 1000 De La Gauchtière St. West, Montreal, QC H3B 0A2 | 1977-08-24 |
Griflin Investments Inc. · Placements Griflin Inc. | 1000 Rue De La GauchetiÈre Street West, MontrÉal, QC H3B 0A2 | |
Find all corporations in postal code H3B 0A2 |
Name | Address |
---|---|
LOUIS AUBUCHON | 4837, COLLÈGE-BEAUBOIS, MONTRÉAL QC H8Y 3T2, Canada |
Thierry Brossard | 21, Beauchamp, Mercier QC J6R 2K2, Canada |
Patrick Malo | 8420, rue Charles-Huot, Mirabel QC J7N 3J7, Canada |
Heather McCrory | 3205 - 1 Market Street, Toronto ON M5E 0A2, Canada |
Name | Director Name | Director Address |
---|---|---|
3105725 CANADA INC. | Heather McCrory | 3205 - 1 Market Street, Toronto ON M5E 0A2, Canada |
D.M.C. Transat inc. | LOUIS AUBUCHON | 4500 PROMENADE PATON, APT # 506, LAVAL QC H7W 4Y6, Canada |
JONVIEW CANADA INC. | LOUIS AUBUCHON | 545, BOUL. CRÉMAZIE EST, SUITE 200, MONTRÉAL QC H2M 2W4, Canada |
3105725 CANADA INC. | LOUIS AUBUCHON | 4837, COLLÈGE-BEAUBOIS, MONTRÉAL QC H8Y 3T2, Canada |
3931927 CANADA INC. | LOUIS AUBUCHON | 4500 PROMENADE PATON, APT 506, LAVAL QC H7W 4Y6, Canada |
SCANDINAVE SPA IN WHISTLER INC. | LOUIS AUBUCHON | 545, CRÉMAZIE EST, BUREAU 200, MONTRÉAL QC H2M 2W4, Canada |
Scandinave Spa Calgary Inc. | Louis Aubuchon | 200-545 boul. Crémazie E., Montréal QC H2M 2W4, Canada |
4306317 CANADA INC. | PATRICK MALO | 288 RUE JEAN-MULOIN, LACHENAIS QC J6V 1T6, Canada |
3105725 CANADA INC. | PATRICK MALO | 8420, RUE CHARLES-HUOT, MIRABEL QC J7N 3J7, Canada |
8885630 Canada Inc. | Thierry Brossard | 1000 ch. des Voyageurs, Mont-Tremblant QC J8E 1T2, Canada |
Please comment or provide details below to improve the information on .
Data Provider | Corporations Canada |
Jurisdiction | Canada |
This dataset includes 826 thousand corporation entities registered with Corporations Canada, a division of Innovation, Science and Economic Development Canada. Each corporation is registered with corporation number, corporate name, office address, current status, directors, annual filling dates, etc.